Category:National Historic Landmarks in Maine
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Bundesstaaten der Vereinigten Staaten: Alabama · Alaska · Arizona · Arkansas · Colorado · Connecticut · Delaware · Florida · Georgia · Hawaii · Idaho · Illinois · Indiana · Iowa · Kalifornien · Kansas · Kentucky · Louisiana · Maine · Maryland · Massachusetts · Michigan · Minnesota · Mississippi · Missouri · Montana · Nebraska · Nevada · New Hampshire · New Jersey · New Mexico · New York · North Carolina · North Dakota · Ohio · Oklahoma · Oregon · Pennsylvania · Rhode Island · South Carolina · South Dakota · Tennessee · Texas · Utah · Vermont · Virginia · Washington · West Virginia · Wisconsin · Wyoming – Washington, D.C.
Amerikanische Jungferninseln · Nördliche Marianen · Puerto Rico
Amerikanische Jungferninseln · Nördliche Marianen · Puerto Rico
Wikimedia-Kategorie | |||||
Medium hochladen | |||||
Ist ein(e) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kategorie kombiniert die Themen |
| ||||
| |||||
Unterkategorien
Es werden 33 von insgesamt 33 Unterkategorien in dieser Kategorie angezeigt:
In Klammern die Anzahl der enthaltenen Kategorien (K), Seiten (S), Dateien (D)
A
- American Eagle (ship, 1930) (2 D)
B
- Blaine House (8 D)
- Bowdoin (ship, 1921) (9 D)
C
- Cushnoc Archeological Site (3 D)
F
- Fort Halifax (18 D)
- Fort Western (23 D)
G
- Grace Bailey (ship, 1882) (3 D)
H
- Harpswell Meetinghouse (12 D)
- Winslow Homer Studio (17 D)
I
- Isaac H. Evans (ship, 1886) (3 D)
J
- J. & E. Riggin (ship, 1927) (4 D)
K
- Kennebec Arsenal (5 D)
L
- Lewis R. French (ship, 1871) (14 D)
M
- McIntire Garrison House (8 D)
- McLellan-Sweat Mansion (25 D)
- Mercantile (ship, 1916) (2 D)
- Morse-Libby House (26 D)
N
- Nickels-Sortwell House (9 D)
O
- Old York Gaol (20 D)
- Olson House (9 D)
P
- Portland Observatory (20 D)
S
- Sabbathday Lake Shaker Village (39 D)
- Sarah Orne Jewett House (20 D)
- Stephen Taber (ship, 1871) (6 D)
T
- Tate House (Portland, Maine) (24 D)
W
Medien in der Kategorie „National Historic Landmarks in Maine“
Folgende 14 Dateien sind in dieser Kategorie, von 14 insgesamt.
-
AugustaME CushnocSite.jpg 1.024 × 680; 222 KB
-
BrunswickME ParkerCleavelandHouse.jpg 1.024 × 680; 224 KB
-
Cushnoc Trading Post, Maine Commemorative Tablet.jpeg 1.280 × 960; 241 KB
-
DowHouse.JPG 3.264 × 2.448; 3,92 MB
-
Fort Kent, Fort Kent (Aroostock County, Maine).jpg 1.567 × 1.150; 495 KB
-
FortKentBlockhouse.png 1.104 × 1.134; 555 KB
-
GardinerME EdwinArlingtonRobinsonHouse.jpg 1.024 × 680; 254 KB
-
Lady Pepperell House.jpg 1.356 × 904; 248 KB
-
Lady Pepperrell House.jpg 655 × 421; 60 KB
-
ME18 Olson House, Maine.jpg 750 × 509; 138 KB
-
Norridgewock memorial detail.jpg 4.928 × 3.264; 3,27 MB
-
Norridgewock site.jpg 4.928 × 3.264; 3,39 MB
-
View of Old Point from the Hill.jpg 915 × 507; 129 KB
-
Wickyup 1970.jpg 300 × 307; 40 KB